LE DAUPHINE LIBERE
 
UNITÉ LÉGALE
Dénomination SocialeLE DAUPHINE LIBERE
Siège Social650 ROUTE DE VALENCE
38113 VEUREY-VOROIZE
Forme JuridiqueSA à conseil d'administration (s.a.i.)
Immatriculation1/1/1957
N° SIREN057502742
Capital24769520 EUR
Code NAF58.13Z (NAFRev2)
ActivitéÉdition de journaux
Effectif salarié500 à 999
TVA IntracommunautaireFR43057502742
HISTORIQUE
9/28/2018Changement de catégorie → économie non sociale
1/1/2008Changement d'activité → 58.13Z (NAFRev2)
12/25/2004Changement d'activité → 22.1C (NAFRev1)
1/1/1957Création → LE DAUPHINE LIBERE SA à conseil d'administration (s.a.i.)
OBSERVATIONS
10/08/2022 Dépotle 06/07/1945 LES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINE DU 28/07/1945
REPRÉSENTANTS
typeAdministrateurChristophe, Pascal, Camille VICTOR
né(e) en 05/1965
38113 Veurey-Voroize
FRANCE
typeAdministrateurGilles, Marcel, Lucien CHABERT
né(e) en 08/1952
38240 Meylan
FRANCE
typeCommissaire aux comptes titulaireKPMG SA
2 AV Gambetta
Tour Eqho Paris cedex
92400 Courbevoie
typeAdministrateurAnnabel KAM
né(e) en 12/1988
94340 Joinville-le-Pont
FRANCE
typeAdministrateurFlorence, Sylvie, Janine MARTIN
né(e) en 11/1971
38000 Grenoble
FRANCE
typeAdministrateurJacques, Andre, Joseph GLENAT
né(e) en 05/1952
38000 Grenoble
FRANCE
typeAdministrateurGenevieve, Marie LEFEVRE
né(e) en 10/1954
38700 La Tronche
FRANCE
typePrésident du conseil d’administrationPauline, Marie, Arlette MAITRE
né(e) en 10/1982
75001 Paris
FRANCE
BÉNÉFICIAIRES
typeL'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF.
Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire.
Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici :
ACTES - (87 actes dans 54 dépôts)
pdfProcès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des commissaires aux comptes
pdfExtrait de procès-verbal du conseil d'administration
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfExtrait de procès-verbal du conseil d'administration
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfExtrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfProcès-verbal du conseil d'administration
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfExtrait de procès-verbal du conseil d'administration
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfProcès-verbal du conseil d'administration
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfProcès-verbal du conseil d'administration
Modification relative aux dirigeants d'une société

Procès-verbal d'assemblée générale mixte
Modification relative aux dirigeants d'une société

Statuts mis à jour
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfProcès-verbal du conseil d'administration
Modification relative aux dirigeants d'une société

Procès-verbal d'assemblée générale mixte
Modification relative aux dirigeants d'une société

Statuts mis à jour
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfStatuts mis à jour
Décision sur la modification du capital social

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Décision sur la modification du capital social

Procès-verbal du conseil d'administration
Décision sur la modification du capital social
pdfProcès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfProcès-verbal du conseil d'administration
pdfStatuts mis à jour
Modification des activités ou/ et de l'objet social Changement dénomination de la rue suite décision municipale

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Modification des activités ou/ et de l'objet social Changement dénomination de la rue suite décision municipale
pdfProcès-verbal d'assemblée générale mixte
Modification des commissaires aux comptes Renouvellement de mandat
pdfProcès-verbal du conseil d'administration
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfProcès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Reconstitution des capitaux propres Modification relative aux dirigeants d'une société

Procès-verbal du conseil d'administration
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfProcès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Reconstitution des capitaux propres Modification relative aux dirigeants d'une société

Procès-verbal du conseil d'administration
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfProcès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des commissaires aux comptes
pdfExtrait de procès-verbal du conseil d'administration
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfProcès-verbal d'assemblée générale mixte
Continuation de la société malgré les pertes
pdfProcès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Reconstitution des capitaux propres
pdfProcès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Décision sur la modification du capital social

Statuts mis à jour
Décision sur la modification du capital social
pdfRapport du commissaire aux apports
Apport en nature
pdfProcès-verbal d'assemblée générale mixte
Modification des commissaires aux comptes
pdfExtrait de procès-verbal du conseil d'administration
Transmission universelle du patrimoine
pdfStatuts mis à jour
fusion absorption Modification de l'objet social

Déclaration de conformité
fusion absorption Modification de l'objet social

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
fusion absorption Modification de l'objet social
pdfRapport du commissaire à la fusion
fusion absorption
pdfTraité
Apport fusion

Procès-verbal du conseil d'administration
Dissolution de la personne morale

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Dissolution de la personne morale
pdfTraité
Apport fusion

Procès-verbal du conseil d'administration
Dissolution de la personne morale

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Dissolution de la personne morale
pdfTraité
Apport fusion

Procès-verbal du conseil d'administration
Dissolution de la personne morale

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Dissolution de la personne morale
pdfExtrait de procès-verbal d'assemblée générale
Modification relative aux dirigeants d'une société

Procès-verbal du conseil d'administration
Modification relative aux dirigeants d'une société

Lettre de nomination
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfDécision(s) de l'actionnaire unique
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfLettre de nomination
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfExtrait de procès-verbal du conseil d'administration
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfProcès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
fusion absorption

Déclaration de conformité
fusion absorption

Acte sous seing privé
fusion absorption
pdfRapport du commissaire à la fusion
fusion absorption
pdfProcès-verbal du conseil d'administration
Mise en harmonie des statuts
pdfOrdonnance du président
Nomination de commissaire aux apports
pdfOrdonnance du président
Nomination de commissaire aux apports
pdfProcès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfProcès-verbal du conseil d'administration
Modification relative aux dirigeants d'une société

Lettre de démission
Modification relative aux dirigeants d'une société

Lettre de nomination
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfProcès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Conversion du capital en euros Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts

Procès-verbal du conseil d'administration
Conversion du capital en euros Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts

Statuts mis à jour
Conversion du capital en euros Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts
pdfProcès-verbal d'assemblée générale
Modification des dirigeants, organes de contrôle
pdfProcès-verbal du conseil d'administration
Décision sur la modification du capital social Modification des statuts Modification relative aux dirigeants d'une société

Procès-verbal d'assemblée générale
Décision sur la modification du capital social Modification des statuts Modification relative aux dirigeants d'une société

Statuts mis à jour
Décision sur la modification du capital social Modification des statuts Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfProcès-verbal d'assemblée générale
fusion absorption

Déclaration de conformité
fusion absorption

Statuts mis à jour
fusion absorption
pdfActe
fusion absorption

Rapport du commissaire aux apports
fusion absorption
pdfOrdonnance du président
Nomination de commissaire (s) aux comptes
pdfProcès-verbal d'assemblée générale
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfProcès-verbal d'assemblée générale
Modification des dirigeants, organes de contrôle
pdfProcès-verbal d'assemblée générale
Changement de commisaires aux comptes
pdfProcès-verbal d'assemblée générale
Modification relative aux dirigeants d'une société

Procès-verbal du conseil d'administration
Modification relative aux dirigeants d'une société

Statuts mis à jour
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfDL AGO 2023 11 24
pdfExtrait du PV
pdfExtrait du PV
COMPTES
Clôture
31/12/2024
Dépôt
11/07/2025
Clôture
31/12/2023
Dépôt
08/08/2024
Clôture
31/12/2022
Dépôt
26/07/2023
Clôture
31/12/2021
Dépôt
10/08/2022
Clôture
31/12/2020
Dépôt
10/09/2021
Clôture
31/12/2019
Dépôt
04/08/2020
Clôture
31/12/2016
Dépôt
20/07/2017
ETABLISSEMENTS
05750274200364
(siège)
58.13ZCréation
1/1/1900
 650 ROUTE DE VALENCE
38113 VEUREY-VOROIZE
05750274201149
(secondaire)
58.13ZCréation
10/1/2024
 164 AVENUE HENRI FALCOZ
73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
05750274201123
(secondaire)
58.13ZCréation
4/1/2024
 PLACE ROBERT SCHUMAN
IMMEUBLE LE PULSAR EUROPOLE - B3
38000 GRENOBLE
05750274201107
(secondaire)
58.13ZCréation
10/1/2022
 455 CHEMIN DE LA CASSINE
73000 CHAMBERY
05750274201099
(secondaire)
58.13ZCréation
3/1/2020
 105 RUE DE L'ARVE
74300 CLUSES
05750274201081
(secondaire)
58.13ZCréation
7/1/2018
 32 RUE GUSTAVE EIFFEL
38100 GRENOBLE
05750274201073
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2016
 260 RUE DU LYRET
RESIDENCE LE LYRET II - BAT B
74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
05750274201065
(secondaire)
58.13ZCréation
6/1/2016
 2 AVENUE DE L'EUROPE UNIE
07000 PRIVAS
05750274201040
(secondaire)
58.13ZCréation
6/1/2015
 46 AVENUE EMILE LACHAUX
84500 BOLLENE
05750274201032
(secondaire)
58.13ZCréation
1/1/2014
 88 BOULEVARD GEORGES POMPIDOU
05000 GAP
05750274201024
(secondaire)
58.13ZCréation
8/1/2013
 34 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE
07100 ANNONAY
05750274201008
(secondaire)
58.13ZCréation
3/1/2013
 5 RUE VICTOR CAMILLE ARTIGE
07200 AUBENAS
05750274200992
(secondaire)
58.13ZCréation
11/1/2012
 29 RUE VICTOR MOLLARD
38500 VOIRON
05750274200968
(secondaire)
58.13ZCréation
5/1/2012
 2 AV I ET FREDERIC JOLIOT CURIE
26700 PIERRELATTE
05750274200950
(secondaire)
58.13ZCréation
5/1/2012
 8 RUE BAUDIN
2EME ETAGE
26000 VALENCE
05750274200943
(secondaire)
58.13ZCréation
5/1/2012
 27 COTE DES CORDELIERS
26100 ROMANS-SUR-ISERE
05750274200935
(secondaire)
58.13ZCréation
5/1/2012
 33 RUE DE L'HOTEL DE VILLE
26400 CREST
05750274200976
(secondaire)
58.13ZCréation
5/1/2012
 13 AVENUE EMILE ZOLA
BATIMENT ETOILE DU SUD
74100 ANNEMASSE
05750274200919
(secondaire)
58.13ZCréation
4/1/2011
 19 AVENUE DU GRAND TISSAGE
38300 BOURGOIN-JALLIEU
05750274200901
(secondaire)
58.13ZCréation
4/1/2011
 30 AVENUE GENERAL LECLERC
38200 VIENNE
05750274200885
(secondaire)
58.13ZCréation
9/22/2009
 23 RUE DE LA REPUBLIQUE
84000 AVIGNON
05750274200836
(secondaire)
58.13ZCréation
9/16/2008
 2 RUE BARTHELEMY CHAIX
IMMEUBLE CENTRAL PARC
05100 BRIANCON
05750274200851
(secondaire)
58.13ZCréation
6/24/2008
 15 PLACE DE LA GARE
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
05750274200844
(secondaire)
63.99ZCréation
4/8/2008
 95 BOULEVARD EDOUARD DALADIER
84100 ORANGE
05750274200828
(secondaire)
58.13ZCréation
2/1/2008
 33 AVENUE CHARLES DE GAULLE
26200 MONTELIMAR
05750274200661
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
 1 RUE JEAN JAURES
CENTRE BONLIEU
74000 ANNECY
05750274200562
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
 5 RUE DES RECOLLETS
38110 LA TOUR-DU-PIN
05750274200778
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
 161 PLACE FODERE
NOUVELLES ARCADES
73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
05750274200711
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
 8 BOULEVARD DU THEATRE
73000 CHAMBERY
05750274200752
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
 51 PLACE DE L'EUROPE
73200 ALBERTVILLE
05750274200802
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
 4 AVENUE SAINT-FRANCOIS DE SALES
74200 THONON-LES-BAINS
05750274201057
(secondaire)
58.13ZCréation
9/1/2015
Fermeture
2/28/2018
79 RUE CLOVIS HUGUES
05200 EMBRUN
05750274201016
(secondaire)
58.13ZCréation
8/1/2013
Fermeture
9/1/2022
8 AVENUE DU PETIT PORT
73100 AIX-LES-BAINS
05750274200984
(secondaire)
58.13ZCréation
11/1/2012
Fermeture
4/1/2015
6 RUE DE VENTADOUR
75001 PARIS
05750274200927
(secondaire)
58.13ZCréation
4/1/2011
Fermeture
10/1/2014
18 RUE VICTOR LEYDET
13100 AIX-EN-PROVENCE
05750274200893
(secondaire)
58.13ZCréation
12/13/2010
Fermeture
9/28/2018
3 RUE DU ONZE NOVEMBRE
26600 TAIN-L'HERMITAGE
05750274200869
(secondaire)
58.13ZCréation
3/3/2009
Fermeture
9/1/2022
80 PLACE CHARLES ALBERT
74700 SALLANCHES
05750274200877
(secondaire)
58.13ZCréation
3/3/2009
Fermeture
9/28/2018
13 PL DES ARCADES
26110 NYONS
05750274200646
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
Fermeture
4/8/2008
38 RUE CARISTIE
84100 ORANGE
05750274200653
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
Fermeture
9/1/2022
111 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
84200 CARPENTRAS
05750274200612
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
Fermeture
4/1/2011
PLACE DES MOULINS
26400 CREST
05750274200505
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
Fermeture
1/1/2014
1 AVENUE JEAN JAURES
05000 GAP
05750274200679
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
Fermeture
5/1/2012
7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
26700 PIERRELATTE
05750274200760
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
Fermeture
6/24/2008
73 SQUARE DE LA LIBERTE
73600 MOUTIERS
05750274200620
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
Fermeture
8/1/2013
22 RUE MONTGOLFIER
07100 ANNONAY
05750274200554
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
Fermeture
4/1/2011
33 COURS ROMESTANG
38200 VIENNE
05750274200687
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
Fermeture
2/28/2018
PLACE FREDERIC MISTRAL
04400 BARCELONNETTE
05750274200703
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
Fermeture
8/1/2013
5 AVENUE CHARLES DE GAULLE
73100 AIX-LES-BAINS
05750274200489
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
Fermeture
11/1/2012
2 RUE DES TERREAUX
38500 VOIRON
05750274200638
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
Fermeture
6/1/2015
PL REYNAUD DE LA GARDETTE
84500 BOLLENE
05750274200695
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
Fermeture
9/22/2009
17 RUE DE LA REPUBLIQUE
84000 AVIGNON
05750274200521
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
Fermeture
5/1/2012
10 COURS PIERRE DIDIER
26100 ROMANS-SUR-ISERE
05750274200794
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
Fermeture
3/2/2009
29 RUE NATIONALE
74500 EVIAN-LES-BAINS
05750274200810
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
Fermeture
3/1/2013
PLACE GENERAL DE-GAULLE
07200 AUBENAS
05750274200745
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
Fermeture
12/31/2020
19 RUE NICOLAS GIROD
74300 CLUSES
05750274200596
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
Fermeture
9/24/2008
AVENUE VOLTAIRE
01210 FERNEY-VOLTAIRE
05750274200497
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
Fermeture
7/1/2018
40 AVENUE ALSACE LORRAINE
38000 GRENOBLE
05750274200513
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
Fermeture
9/16/2008
PLACE CENTRALE
05100 BRIANCON
05750274200729
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
Fermeture
12/1/2016
19 AVENUE MICHEL CROZ
BP 63
74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
05750274200588
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
Fermeture
12/19/2008
CTRE COMMERCIAL DE ST BONNET
38090 VILLEFONTAINE
05750274200737
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
Fermeture
6/15/2008
57 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
74130 BONNEVILLE
05750274200539
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
Fermeture
5/1/2012
13 BOULEVARD MAURICE CLERC
26000 VALENCE
05750274200547
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
Fermeture
4/1/2011
10 AVENUE DU GRAND TISSAGE
38300 BOURGOIN-JALLIEU
05750274200570
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
Fermeture
9/28/2018
PL DE LA HALLE FRANCOIS MITTERRAND
38550 LE PEAGE-DE-ROUSSILLON
05750274200604
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
Fermeture
9/1/2022
55 B RUE DE LA REPUBLIQUE
01200 VALSERHONE
05750274200786
(secondaire)
58.13ZCréation
12/1/2006
Fermeture
5/1/2012
36 AVENUE DE LA GARE
74100 ANNEMASSE
05750274200471
(secondaire)
68.20BCréation
1/1/2003
Fermeture
5/1/2011
168 AVENUE HENRI FALCOZ
73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
05750274200463
(secondaire)
22.1CCréation
8/1/1992
Fermeture
12/31/1996
17 AVENUE DU GENERAL MANGIN
75016 PARIS
05750274200448
(secondaire)
58.13ZCréation
10/3/1989
Fermeture
2/3/2008
5 PLACE LEOPOLD BLANC
26200 MONTELIMAR
05750274200430
(secondaire)
22.1CCréation
11/28/1988
Fermeture
6/22/1994
62 RUE DU LOUVRE
75002 PARIS
05750274200455
(secondaire)
22.1CCréation
11/25/1988
Fermeture
8/1/1992
62 RUE DU LOUVRE
75002 PARIS
05750274200414
(secondaire)
22.1CCréation
7/1/1985
Fermeture
12/25/1993
100 RUE REAUMUR
75002 PARIS
05750274200406
(secondaire)
58.13ZCréation
3/1/1984
Fermeture
12/19/2008
12 RUE DE LA CHARITE
69002 LYON
05750274200257
(secondaire)
58.13ZCréation
1/1/1900
Fermeture
12/19/2008
2 PLACE CHARLIE CHAPLIN
38300 BOURGOIN-JALLIEU
05750274200075
(secondaire)
58.13ZCréation
1/1/1900
Fermeture
2/13/2009
35 GRANDE RUE
74200 THONON-LES-BAINS
05750274200190
(secondaire)
22.1CCréation
1/1/1900
Fermeture
6/22/1994
5 PL DU GARDE TEMPS
43200 YSSINGEAUX
05750274200109
(secondaire)
58.13ZCréation
1/1/1900
Fermeture
2/13/2009
5 RUE DE LA GARE
74100 ANNEMASSE
05750274200216
(secondaire)
22.1CCréation
1/1/1900
Fermeture
12/25/1993
16 PLACE JEAN JAURES
42000 SAINT-ETIENNE
05750274200299
(secondaire)
58.13ZCréation
1/1/1900
Fermeture
6/1/2016
6 COURS DE L'ESPLANADE
07000 PRIVAS
05750274200182
(secondaire)
22.1CCréation
1/1/1900
Fermeture
12/25/1994
14 RUE DE LA CHARITE
69002 LYON