SPIE SUD-OUEST
 
UNITÉ LÉGALE
Dénomination SocialeSPIE SUD-OUEST
Siège Social70 CHE DE PAYSSAT
ZI DE MONTAUDRAN
31000 TOULOUSE
Forme JuridiqueSAS, société par actions simplifiée
Immatriculation10/9/2001
N° SIREN440056463
Code NAF43.21A (NAFRev2)
ActivitéTravaux d'installation électrique dans tous locaux
Effectif salariéInconnu
TVA IntracommunautaireFR80440056463
HISTORIQUE
6/30/2018Fermeture ou mise en sommeil de la société
5/1/2017Changement de catégorie → économie non sociale
1/1/2008Changement d'activité → 43.21A (NAFRev2)
9/14/2006Changement de dénomination sociale → SPIE SUD-OUEST
1/1/2004Transfert de siège → 440056463 00050
12/25/2003Changement d'activité → 45.3A (NAFRev1)
1/1/2003Changement de dénomination sociale → AMEC SPIE SUD OUEST
12/25/2001Changement d'activité → 74.2C (NAF1993)
10/9/2001Création → ST 11 SAS, société par actions simplifiée
ACTES - (50 actes dans 37 dépôts)
pdfDéclaration de conformité
Radiation de la personne morale par suite de fusion

Décision(s) de l'associé unique
Radiation de la personne morale par suite de fusion
pdfTraité de fusion
fusion absorption
pdfDécision(s) de l'associé unique
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfDéclaration de conformité
Apport partiel d'actif placé sous le régime des fusions/scissions

Décision(s) de l'associé unique
Apport partiel d'actif placé sous le régime des fusions/scissions
pdfDéclaration de conformité
Apport partiel d'actif placé sous le régime des fusions/scissions

Décision(s) de l'associé unique
Apport partiel d'actif placé sous le régime des fusions/scissions
pdfProjet
Apport partiel d'actif Divers Divers
pdfProjet
Apport partiel d'actif Divers Divers
pdfDécision(s) de l'associé unique
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfStatuts mis à jour
Modification des statuts

Décision(s) de l'associé unique
Modification des statuts
pdfActe
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfStatuts mis à jour
Modification des statuts

Extrait de décision(s) de l'associé unique
Modification des statuts
pdfStatuts mis à jour
Modification des statuts

Extrait de décision(s) de l'associé unique
Modification des statuts
pdfActe
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfStatuts mis à jour
Modification des statuts

Rapport
Modification des statuts

Extrait de décision(s) de l'associé unique
Modification des statuts
pdfActe
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfProcès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Refonte des statuts

Statuts mis à jour
Refonte des statuts
pdfExtrait de décision(s) de l'associé unique
Modification des statuts

Statuts mis à jour
Modification des statuts
pdfStatuts mis à jour
Modification de la dénomination de la personne morale

Décision(s) de l'associé unique
Modification de la dénomination de la personne morale
pdfDécision(s) de l'actionnaire unique
Modification des statuts

Statuts mis à jour
Modification des statuts
pdfDivers
Divers
pdfDécision(s) de l'associé unique
Transfert du siège social de la personne morale
pdfmo81QvC30ElL RACT0500441417
pdfNWKHTR7wXko5 RACT0400784489
pdfOmltA8Kev4nG RACT0401067549
pdf2SHShZGU8ITM RACT0400589009
pdfxqbYr1EaD9dW RACT0400156964
pdf6yBHSJ4jJ9d8 RACT0400035573
pdfHM9lNOqdBjdS RACT0400296158
pdfwLCX9bwpbAaf RACT0400033874
pdfUVgnfaaNjbj9 RACT0400730342
pdfJfzYMgFCbB0Z RACT0400184198
pdfzAP78JhxOted RACT0300744859
pdfseUWQ8rMyNNT RACT0300534926
pdfPWbSQ1mqa1tE RACT0300025681
pdfuqKdi7drPYUP RACT0300288893
pdf34LXJ2QDdrla RACT0300288896
pdfWCRyOMytbmI6 RACT0300007265
pdfMLUK0GRD84kY RACT0100957674
COMPTES
Clôture
31/12/2017
Dépôt
11/06/2018
Clôture
31/12/2016
Dépôt
22/06/2017
ETABLISSEMENTS
44005646300050
(siège)
43.21ACréation
6/30/2003
Fermeture
6/30/2018
70 CHE DE PAYSSAT
ZI DE MONTAUDRAN
31000 TOULOUSE
44005646300431
(secondaire)
43.21ACréation
5/1/2017
Fermeture
6/30/2018
556 CHE DU MAS DE CHEYLON
CAP DELTA
30000 NIMES
44005646300449
(secondaire)
43.21ACréation
5/1/2017
Fermeture
6/30/2018
2 CHE DE PERBOST
ZI PERBOST
31800 LABARTHE-INARD
44005646300423
(secondaire)
35.11ZCréation
1/5/2016
Fermeture
6/30/2018
DOM DE MALAKOF
11100 NARBONNE
44005646300415
(secondaire)
43.21ACréation
6/1/2015
Fermeture
6/30/2018
17 AV DE L AERODROME
ZI MIRANDE II
66240 SAINT-ESTEVE
44005646300407
(secondaire)
43.21ACréation
2/1/2012
Fermeture
9/30/2017
23 RTE DE LA JAUGUEYRE
33650 MARTILLAC
44005646300399
(secondaire)
43.21ACréation
1/10/2011
Fermeture
8/31/2011
4 IMP DU PONTET
81210 ROQUECOURBE
44005646300381
(secondaire)
43.21ACréation
7/1/2010
Fermeture
6/30/2018
6 RUE JULES VEDRINES
31000 TOULOUSE
44005646300373
(secondaire)
43.21ACréation
2/1/2010
Fermeture
6/30/2018
162 RUE PHILIBERT DELORME
VILLAGE D ENTREPRISES
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX
44005646300365
(secondaire)
43.21ACréation
1/12/2010
Fermeture
6/30/2018
600 CHE BARTHELOT - COULASSY
82800 NEGREPELISSE
44005646300357
(secondaire)
43.21ACréation
1/12/2009
Fermeture
9/30/2017
219 CHE DE LA PRAIRIE
34380 SAINT-MARTIN-DE-LONDRES
44005646300340
(secondaire)
43.21ACréation
7/1/2008
Fermeture
6/30/2014
7 RUE DE LA GRANDE TERRE
ZONE EURO 2000
30132 CAISSARGUES
44005646300332
(secondaire)
28.41ZCréation
1/1/2008
Fermeture
3/31/2008
6 PL DU MARCHE AU BOIS
09100 PAMIERS
44005646300324
(secondaire)
43.21ACréation
1/1/2007
Fermeture
9/30/2017
8 AV DE PRADIE
ZI DU BOIS VERT
31120 PORTET-SUR-GARONNE
44005646300316
(secondaire)
43.21ACréation
12/1/2005
Fermeture
5/1/2017
ZI PERBOST N 22
31800 LABARTHE-INARD
44005646300308
(secondaire)
43.21ACréation
1/1/2004
Fermeture
1/1/2008
LABESCOU
81100 CASTRES
44005646300290
(secondaire)
45.3ACréation
1/1/2004
Fermeture
12/31/2006
15 RUE ALFRED SAUVY
31270 CUGNAUX
44005646300282
(secondaire)
82.11ZCréation
12/11/2003
Fermeture
6/30/2018
70 CHE DE PAYSSAT
BUREAUX ADMINISTRATIFS
31000 TOULOUSE
44005646300035
(secondaire)
43.21ACréation
6/30/2003
Fermeture
7/1/2010
75 CHE DE PAYSSAT
31000 TOULOUSE
44005646300084
(secondaire)
43.21ACréation
6/30/2003
Fermeture
1/1/2010
172 RUE CHARLES TELLIER
ZI LE LUGAN
33130 BEGLES
44005646300209
(secondaire)
43.21ACréation
6/30/2003
Fermeture
6/30/2018
PEYRE PLANTADE
18 R DE LA RIJOLE
09100 PAMIERS
44005646300258
(secondaire)
43.21ACréation
6/30/2003
Fermeture
9/30/2017
46 AV DE LA MERIDIENNE
ZONE ACTIVITE
48100 MARVEJOLS
44005646300183
(secondaire)
45.3ACréation
6/30/2003
Fermeture
12/1/2005
16 BD CHARLES DE GAULLE
31800 SAINT-GAUDENS
44005646300092
(secondaire)
43.21ACréation
6/30/2003
Fermeture
6/30/2018
RUE DENIS PAPIN
ZI JEAN MALEZE
47240 BON-ENCONTRE
44005646300191
(secondaire)
43.21ACréation
6/30/2003
Fermeture
2/1/2010
1313 BD SAINT VINCENT DE PAUL
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX
44005646300100
(secondaire)
43.21ACréation
6/30/2003
Fermeture
6/30/2018
ZONE INDUSTRIEL PLAISANCE
11100 NARBONNE
44005646300241
(secondaire)
43.21ACréation
6/30/2003
Fermeture
6/30/2018
14 AV DU TINDOUL
12740 SEBAZAC-CONCOURES
44005646300217
(secondaire)
43.21ACréation
6/30/2003
Fermeture
1/1/2008
86 RTE DE MONTPELLIER
34200 SETE
44005646300027
(secondaire)
45.3ACréation
6/30/2003
Fermeture
12/31/2004
9 IMP LOUIS DE FROIDOUR
31000 TOULOUSE
44005646300076
(secondaire)
43.21ACréation
6/30/2003
Fermeture
6/30/2018
RUE ALFRED DE MUSSET
ZI THOUARS
33400 TALENCE
44005646300175
(secondaire)
43.21ACréation
6/30/2003
Fermeture
9/30/2017
PROM SAINT MARTIN
82200 MOISSAC
44005646300118
(secondaire)
43.21ACréation
6/30/2003
Fermeture
6/30/2018
RUE DE BIELLE
ZI HAUT D OSSAU
64121 SERRES-CASTET
44005646300134
(secondaire)
43.21ACréation
6/30/2003
Fermeture
6/30/2018
LD LA PORTE
24430 RAZAC SUR L'ISLE
44005646300142
(secondaire)
43.21ACréation
6/30/2003
Fermeture
6/1/2015
RUE DE LA SALANQUE
ZONE ARTISANALE
66300 THUIR
44005646300043
(secondaire)
45.3ACréation
6/30/2003
Fermeture
1/1/2007
10 AV DE PRADIE
PARC ACTIVITES BOIS VERT
31120 PORTET-SUR-GARONNE
44005646300167
(secondaire)
43.21ACréation
6/30/2003
Fermeture
9/30/2017
RTE D'AUCH
ZA JAMON
32310 VALENCE-SUR-BAISE
44005646300225
(secondaire)
43.21ACréation
6/30/2003
Fermeture
6/30/2018
RUE DE PITOYS
ZAC DE MAIGNON
64600 ANGLET
44005646300159
(secondaire)
43.21ACréation
6/30/2003
Fermeture
1/1/2008
5 T RUE DE L INDUSTRIE
66240 SAINT-ESTEVE
44005646300068
(secondaire)
43.21ACréation
6/30/2003
Fermeture
6/30/2018
170 RUE HENRI FARMAN
PARC MARCEL DASSAULT
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
44005646300233
(secondaire)
43.21ACréation
6/30/2003
Fermeture
7/1/2008
97 RTE DE CLERMONT
34600 BEDARIEUX
44005646300126
(secondaire)
43.21ACréation
6/30/2003
Fermeture
5/1/2017
250 CHE DU MAS DE DEVEZE
30000 NIMES
44005646300266
(secondaire)
43.21ACréation
6/30/2003
Fermeture
6/30/2018
50 AV VINCENT D INDY
30100 ALES
44005646300274
(secondaire)
43.21ACréation
6/30/2003
Fermeture
6/30/2018
42 CHE ALBERT EINSTEIN
SITE INDUSTRIELLE RANTEIL
81000 ALBI
44005646300019
(secondaire)
45.3ACréation
10/9/2001
Fermeture
7/1/2005
10 AV DE L ENTREPRISE
95000 CERGY