DISTRIBUTION DE MATERIAUX POUR LES TRAVAUX PUBLICS - D.M.T.P
 
UNITÉ LÉGALE
Dénomination SocialeDISTRIBUTION DE MATERIAUX POUR LES TRAVAUX PUBLICS - D.M.T.P
Siège Social3 RUE DENIS PAPIN
ZI N0 1
37300 JOUE-LES-TOURS
Forme JuridiqueSAS, société par actions simplifiée
Immatriculation9/21/2007
N° SIREN500168463
Capitalundefined undefined
Code NAF46.73A (NAFRev2)
ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Effectif salarié1 ou 2
TVA IntracommunautaireFR82500168463
HISTORIQUE
1/12/2022Transfert de siège → 50016846300957
11/29/2019Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée
6/1/2019Transfert de siège → 50016846300031
12/31/2017Changement de catégorie → économie non sociale
12/15/2008Changement de forme → Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle
1/7/2008Changement d'activité → 46.73A (NAFRev2)
1/1/2008Changement d'activité → 64.20Z (NAFRev2)
10/24/2007Transfert de siège → 50016846300023
10/24/2007Changement de dénomination sociale → DISTRIBUTION DE MATERIAUX POUR LES TRAVAUX PUBLICS - D.M.T.P
9/21/2007Création → ORLONA SAS SAS, société par actions simplifiée
OBSERVATIONS
22/06/2020 Numéro de gestion au Rcs de Paris 07b22984
BÉNÉFICIAIRES
typeL'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF.
Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire.
Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici :
ACTES - (71 actes dans 49 dépôts)
pdfProcès-verbal d'assemblée générale
pdfProjet de traité de fusion
Projet de fusion entre FRANS BONHOMME société absorbante et DISTRIBUTION DE MATERIAUX POUR LES TRAVAUX PUBLICS société absorbée
pdfDécision(s) du président
Transfert du siège social d'un greffe extérieur

Statuts mis à jour

Liste des sièges sociaux antérieurs
pdfDécision(s) de l'associé unique
Changement de président

Décision(s) de l'associé unique
Démission de directeur général
pdfDécision(s) des associés
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

Décision(s) des associés
Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire

Décision(s) des associés
Rectification d'une erreur matérielle constatée dans le procès-verbal de la consultation par correspondance des associés du 06 Mai 2019
pdfDécision(s) des associés
Renouvellement de mandat de président

Décision(s) des associés
Renouvellement de mandat de directeur général

Décision(s) des associés
Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes

Décision(s) des associés
Transfert du siège social

Décision(s) des associés
Modification(s) statutaire(s)

Statuts mis à jour

Liste des sièges sociaux antérieurs
pdfDécision(s) du président
Transfert du siège social
pdfProcès-verbal
Changement de directeur général
pdfProcès-verbal
Augmentation du capital social

Procès-verbal
Modification(s) statutaire(s)

Déclaration de conformité

Traité
Fusion définitive

Statuts mis à jour
pdfRapport du commissaire à la fusion
pdfProjet de traité de fusion
pdfProcès-verbal
Changement de président
pdfOrdonnance
Nomination de commissaire aux apports
pdfepE9tqpsxFsP C0022A1001L362973D20160927H165716TPIJTES003PDBOR
pdf46715875000000 C0022A1001L077545D20140704H200915TPIJTES003PDBOR
pdf1tm29fEbDYgX RACT2 500168463 7501 2007B22984 2011 9643001
pdfE98cMExJn5Yf RACT2 500168463 7501 2007B22984 2011 1055801
pdfVFnAM5XzIvHG RACT2 500168463 7501 2007B22984 2009 10302301
pdfoo0MmFLFVRLw RACT2 500168463 7501 2007B22984 2009 7318601
pdfI6s5yIjITvza RACT0900298692
pdfLkMSfKGBYC3B RACT0800810278
pdf6qizCfVcldiN RACT0800810279
pdfBiIce3HUjK5Y RACT0800810282
pdfNOmlP9z5jZ60 RACT0800810289
pdfjVPE6oYQ5mWZ RACT0800810298
pdfVggElie7NCGf RACT0800810288
pdf2toV2gNGQLFn RACT0800810287
pdfYgNOHLcpPFWY RACT0800810286
pdf9pRh3yI6hRl2 RACT0800810283
pdfoYcvwrn5r0OO RACT0800810284
pdfvGJkpCsDQ4eF RACT0800810285
pdfARWrrnQe54C7 RACT0800351914
pdfIkV6lUMRLufy RACT0801194374
pdfVN9QkEKvsMB6 RACT0801194376
pdfIWd6DfLIfhq6 RACT0801194377
pdf5Q5YTKc3UYyr RACT0801194379
pdfKk8jIQj00Veo RACT0801194381
pdfA3P7JLR9SpOJ RACT0801194383
pdf5kSqRij8WC9e RACT0801194384
pdftdxhC3XrrXwC RACT0801194387
pdfsGU28GziupEq RACT0801194388
pdfF3T8lMjbydib RACT0801194391
pdfTmVXdzdOpZ5m RACT0800371172
pdfDmRLA88yKqoQ RACT0801233420
pdfTCHLS0bFgOT7 RACT0800172110
pdfuWdytt3yHcfM RACT0800158830
pdfProcès-verbal
Modification(s) statutaire(s)

Procès-verbal
Nomination de directeur général

Statuts mis à jour
pdfStatuts mis à jour

Décision(s) de l'actionnaire unique
Changement de président

Décision(s) de l'actionnaire unique
Changement de la dénomination sociale ORLONA SAS

Décision(s) de l'actionnaire unique
Changement relatif à l'objet social

Décision(s) de l'actionnaire unique
Transfert du siège social d'un greffe extérieur Les Miroirs 18 avenue d'Alsace 92400 COURBEVOIE

Décision(s) de l'actionnaire unique
Modification(s) statutaire(s)
pdfRVr87hoFtL6l RACT0700156570
COMPTES
Clôture
31/12/2019
Dépôt
04/12/2020
Clôture
31/12/2018
Dépôt
23/10/2019
Clôture
31/12/2017
Dépôt
31/07/2018
BODACC
7/8/2022TOURSVentes et cessions
4/17/2022TOURSModifications diverses
11/6/2022TOURSRadiations
7/8/2022TOURSVentes et cessions
7/10/2022MELUNVentes et cessions
11/17/2021QUIMPERVentes et cessions
3/7/2021QUIMPERVentes et cessions
1/17/2020BOBIGNYModifications diverses
12/8/2020BOBIGNYDépôts des comptes
8/14/2020ORLÉANSProcédures de conciliation
1/9/2020BOBIGNYModifications diverses
7/21/2020RODEZVentes et cessions
11/8/2019PARISDépôts des comptes
1/8/2019PARISModifications diverses
2/10/2019PARISModifications diverses
12/20/2019BOBIGNYModifications diverses
8/23/2018PARISDépôts des comptes
2/11/2018PARISModifications diverses
9/2/2018PARISVentes et cessions
9/4/2018MELUNVentes et cessions
9/26/2017PARISDépôts des comptes
9/21/2016PARISModifications diverses
9/7/2016PARISDépôts des comptes
10/17/2015PARISDépôts des comptes
11/28/2014PARISDépôts des comptes
4/7/2013PARISModifications diverses
11/19/2013PARISDépôts des comptes
8/15/2012PARISDépôts des comptes
2/18/2011PARISModifications diverses
10/15/2011PARISDépôts des comptes
10/30/2011PARISModifications diverses
9/29/2010PARISDépôts des comptes
5/16/2010GRENOBLEVentes et cessions
5/6/2010CHAMBERYVentes et cessions
4/19/2009BORDEAUXModifications diverses
4/19/2009BORDEAUXModifications diverses
12/20/2009PARISModifications diverses
9/13/2009PARISModifications diverses
4/19/2009BORDEAUXModifications diverses
4/26/2009PARISModifications diverses
12/23/2009PARISDépôts des comptes
8/26/2008PARISModifications diverses
5/20/2008PARISImmatriculations
10/13/2008PARISModifications diverses
8/26/2008PARISModifications diverses
4/23/2008BRIVEVentes et cessions
6/27/2008FREJUSVentes et cessions
ETABLISSEMENTS
FRANS BONHOMME
50016846300957
(siège)
46.73ACréation
11/1/2021
 3 RUE DENIS PAPIN
ZI N0 1
37300 JOUE-LES-TOURS
FRANS BONHOMME
50016846300932
(secondaire)
46.73ACréation
11/1/2021
 36 AVENUE RAYMOND POINCARE
75016 PARIS
50016846300940
(secondaire)
46.73ACréation
11/1/2021
 274 AVENUE DE LA COTE D’ARGENT
33380 BIGANOS
50016846300924
(secondaire)
46.73ACréation
3/1/2021
 RUE DE LA FORET
ZA L'OREE DU BOIS
25480 PIREY
50016846300916
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2021
 475 RUE RAYMOND HERVILLARD
77000 VAUX-LE-PENIL
50016846300908
(secondaire)
46.73ACréation
9/1/2020
 7 IMPASSE LEON FOUCAULT
ZI EUROCHANNEL
76370 DIEPPE
50016846300890
(secondaire)
23.61ZCréation
10/5/2018
 RUE BENJAMIN FRANKLIN
ZI DE BEL AIR CHEMIN PET AU DIABLE
77000 LA ROCHETTE
POINT.P TRAUVAUX PUBLICS
50016846300882
(secondaire)
46.73ACréation
11/15/2017
 2 RUE AUGUSTIN FRESNEL
69680 CHASSIEU
POINT.P TRAVAUX PUBLICS
50016846300874
(secondaire)
46.73ACréation
2/1/2017
 53 QUAI DE L’APPORT PARIS
91100 CORBEIL-ESSONNES
50016846300866
(secondaire)
46.73ACréation
6/1/2015
 1 RUE DENIS PAPIN
ZA DE SAINT LEONARD
56450 THEIX-NOYALO
POINT P. TRAVAUX PUBLICS
50016846300841
(secondaire)
46.73ACréation
6/1/2013
 IMPASSE DES PETITS MARAIS
PORT DE GENNEVILLIERS
92230 GENNEVILLIERS
50016846300833
(secondaire)
46.73ACréation
12/1/2012
 4 RUE COLBERT
91320 WISSOUS
50016846300825
(secondaire)
46.73ACréation
10/1/2012
 4 BOULEVARD JEAN MOULIN
ZONE OUEST DE MALLEVE
44100 NANTES
POINT P TP
50016846300817
(secondaire)
46.73ACréation
7/1/2012
 58 ROUTE DE BELLEVUE
16710 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE
50016846300791
(secondaire)
46.73ACréation
7/1/2010
 2 RUE DES CRUCHETS
ZA DE LA BARRICADE
22170 PLERNEUF
50016846300783
(secondaire)
46.73ACréation
4/1/2010
 CHEMIN DE LA SAINT-MARTIN
ZI DE L'ALBANNE
73190 SAINT-BALDOPH
POINT P TP
50016846300759
(secondaire)
46.73ACréation
1/5/2009
 8 B RUE DU BIGARREAU
68260 KINGERSHEIM
POINT P TP
50016846300742
(secondaire)
46.73ACréation
1/4/2009
 12 RUE LEON FOURNIER
38130 ECHIROLLES
POINT P TP
50016846300767
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2009
 7 RUE DES LOYES
ZA DU CHAMP LAMET
63430 PONT-DU-CHATEAU
50016846300734
(secondaire)
46.73ACréation
4/1/2008
 RTE DE SARREBRUCK
ZA DE LA PLANCHETTE
57530 OGY-MONTOY-FLANVILLE
50016846300569
(secondaire)
46.73ACréation
3/1/2008
 11 RUE PAUL ROCACHE
ZI DE MONLONG
31100 TOULOUSE
50016846300510
(secondaire)
46.73ACréation
3/1/2008
 110 RUE DE PARIS
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
50016846300437
(secondaire)
46.73ACréation
3/1/2008
 41 RUE DE GODE
95100 ARGENTEUIL
50016846300429
(secondaire)
46.73ACréation
3/1/2008
 12 RUE LOUIS THEBAULT
94370 SUCY-EN-BRIE
50016846300544
(secondaire)
46.73ACréation
3/1/2008
 475 AVENUE DE MILAN
MAS DE BRUNO
66000 PERPIGNAN
50016846300627
(secondaire)
46.73ACréation
3/1/2008
 CHEMIN DE HALAGE
PARC D ACTIVITES DU JONQUAY II
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
50016846300486
(secondaire)
46.73ACréation
3/1/2008
 10 RUE DE LA CHAMOISERIE
CD43
78920 ECQUEVILLY
50016846300577
(secondaire)
46.73ACréation
3/1/2008
 6 CHEMIN DU PARC
ET 13 AVENUE DU PETIT PARADIS
31150 BRUGUIERES
POINT.P TRAVAUX PUBLICS
50016846300361
(secondaire)
46.73ACréation
3/1/2008
 98 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER
93420 VILLEPINTE
50016846300478
(secondaire)
46.73ACréation
3/1/2008
 17 RUE FRANCOIS ARAGO
78990 ELANCOURT
50016846300353
(secondaire)
46.73ACréation
3/1/2008
 2 B ROUTE DE LIMOURS
91290 ARPAJON
50016846300494
(secondaire)
46.73ACréation
3/1/2008
 11 RUE DE LA CHAMOISERIE
78920 ECQUEVILLY
50016846300668
(secondaire)
46.73ACréation
3/1/2008
 RUE FREYCINET
ZONE PORTUAIRE
77400 LAGNY-SUR-MARNE
50016846300080
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
 6 RUE BARTHELEMY THIMONNIER
01000 BOURG-EN-BRESSE
50016846300254
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
 AVENUE DE LA ROTONDE
59160 LILLE
50016846300155
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
 268 RUE DE LA CORNAILLERE
45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC
50016846300320
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
 AVENUE DE LA GRANGE NOIRE
33700 MERIGNAC
50016846300411
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
 72 RUE JEAN MERMOZ
45700 VILLEMANDEUR
50016846300601
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
 76 RUE DE LA PLAINE DES BOUCHERS
67100 STRASBOURG
50016846300056
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
 RUE DU MANEGUEN
ZI DE KERPONT
56850 CAUDAN
50016846300163
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
 ZI DE CANTIMPRE
59400 FONTAINE-NOTRE-DAME
50016846300312
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
 ALLEE DU ROYANS
26300 BOURG-DE-PEAGE
50016846300684
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
 31 RUE RUDOLF DIESEL
ZONE INDUSTRIELLE LA PALUD
83600 FREJUS
50016846300122
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
 RTE DE L AEROPORT
RD 20
13127 VITROLLES
50016846300585
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
 RUE DES 40 MINES
ZAC DE THER
60000 ALLONNE
50016846300700
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
 5 AVENUE DE BELLEVUE
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
50016846300064
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
 123 QUAI EMILE CORMERAIS
44800 SAINT-HERBLAIN
50016846300270
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
 LES CONSACS
LOT E7
83170 BRIGNOLES
50016846300205
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
 13 AVENUE DE LA BALLASTIERE
33500 LIBOURNE
50016846300130
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
 2 RUE RENE CASSIN
28000 CHARTRES
50016846300197
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
 55 ROUTE DE L’EVEQUE
24430 MARSAC-SUR-L'ISLE
50016846300304
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
 RUE RENE CASSIN
62230 OUTREAU
50016846300643
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
 1 RUE LEON HENNEBIQUE
24100 BERGERAC
50016846300114
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
 ROUTE NATIONALE 8
LE VAISSEAU
13420 GEMENOS
50016846300213
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
 RUE DES SCIERIES
59640 DUNKERQUE
50016846300403
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
 RN 202
06670 CASTAGNIERS
50016846300650
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
 110 RUE AMPERE
83260 LA CRAU
50016846300171
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
 RUE DU CANAL
80000 AMIENS
50016846300106
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
 521 ROUTE DE PRINGY
74370 ARGONAY
50016846300247
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
 BOULEVARD DU VAL DE VESLE
BD DU VAL DE VESLE PROLONGE
51100 REIMS
50016846300346
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
 22 RUE ANDRE-MARIE AMPERE
ZONE INDUSTDE LA MOULINE- 22 A 24
33560 CARBON-BLANC
50016846300379
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
 6 ALLEE ABBE GREGOIRE
TY NEVEZ
29000 QUIMPER
POINT.P TRAVAUX PUBLICS
50016846300858
(secondaire)
46.73ACréation
3/1/2015
Fermeture
9/1/2020
ZONE INDUSTRIELLE
NEUVILLE LES DIEPPE
76370 ROUXMESNIL-BOUTEILLES
50016846300809
(secondaire)
46.73ACréation
6/20/2011
Fermeture
3/19/2018
ALLEE ERIC TABARLY
33310 LORMONT
50016846300775
(secondaire)
46.73ACréation
4/1/2010
Fermeture
5/4/2011
14 RUE DU PRE BLANCHET
38400 SAINT-MARTIN-D'HERES
POINT P TP
50016846300726
(secondaire)
46.73ACréation
7/25/2008
Fermeture
6/30/2013
CHEMIN DES ARTISANS
44470 CARQUEFOU
50016846300718
(secondaire)
46.73ACréation
6/1/2008
Fermeture
12/1/2012
SAINT MARTIN
LES BERTRANNES
84120 PERTUIS
50016846300676
(secondaire)
46.73ACréation
5/13/2008
Fermeture
5/31/2010
13 RUE DE LA FREBARDIERE
ZI SUD EST
35000 RENNES
50016846300692
(secondaire)
46.73ACréation
4/1/2008
Fermeture
1/1/2021
RUE BENJAMIN FRANKLIN
ZI DE BEL AIR
77000 LA ROCHETTE
50016846300635
(secondaire)
46.73ACréation
3/1/2008
Fermeture
12/31/2018
AVENUE DU CLOS DE LA TETE
ZONE INDUSTRIELLE DU MARTRAY
14730 GIBERVILLE
50016846300502
(secondaire)
46.73ACréation
3/1/2008
Fermeture
2/29/2012
40 RTE NATIONALE 1
95200 SARCELLES
50016846300387
(secondaire)
46.73ACréation
3/1/2008
Fermeture
12/1/2012
37 AVENUE RAYMOND ARON
91300 MASSY
50016846300528
(secondaire)
46.73ACréation
3/1/2008
Fermeture
7/31/2009
RUE HENRI PITOT
Z.I. LA BOURIETTE
11000 CARCASSONNE
50016846300551
(secondaire)
46.73ACréation
3/1/2008
Fermeture
6/30/2020
805 AVENUE DU CAUSSE
12850 ONET-LE-CHATEAU
50016846300148
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
Fermeture
1/1/2009
31 AVENUE DE LA GARE
63430 PONT-DU-CHATEAU
50016846300221
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
Fermeture
5/12/2010
LD LAGRAVIERE
47550 BOE
50016846300460
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
Fermeture
8/31/2012
6 RUE EUGENE SUE
38100 GRENOBLE
50016846300031
(secondaire)
70.10ZCréation
1/1/2008
Fermeture
1/12/2022
4 AVENUE ALBERT EINSTEIN
ZI DU COUDRAY
93150 LE BLANC-MESNIL
50016846300296
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
Fermeture
3/1/2021
7 RUE DENNIS GABOR
25000 BESANCON
50016846300338
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
Fermeture
11/1/2021
137 AVENUE DE LA COTE D’ARGENT
33380 BIGANOS
50016846300395
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
Fermeture
7/1/2012
58 B ROUTE DE BELLEVUE
16710 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE
50016846300536
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
Fermeture
12/31/2009
RUE LAVOISIER
ZONE INDUSTRIELLE
62290 NŒUX-LES-MINES
50016846300049
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
Fermeture
7/1/2010
RUE BERTHOLLET
ZI
22000 SAINT-BRIEUC
50016846300098
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
Fermeture
7/31/2015
37 BOULEVARD BERNARD PALISSY
42300 ROANNE
50016846300593
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
Fermeture
1/31/2009
51 RUE DE LA FERME CLAUS
67500 HAGUENAU
50016846300072
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
Fermeture
1/1/2008
23 BOULEVARD DE LA HAIE DES COGNETS
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
50016846300239
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
Fermeture
7/31/2009
ZONE ARTISANALE DU MEYROL
26200 MONTELIMAR
50016846300262
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
Fermeture
6/30/2008
13 RUE DE LA HAIE PLOUVIER
59810 LESQUIN
50016846300445
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
Fermeture
1/1/2013
RUE DE LA JALESIE
ZA LES ARBLETIERS
25400 AUDINCOURT
50016846300452
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
Fermeture
1/5/2009
118 FAUBOURG DE MULHOUSE
68260 KINGERSHEIM
50016846300189
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
Fermeture
12/31/2017
21 RUE EUGENE HENAFF
69200 VENISSIEUX
50016846300619
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
Fermeture
7/2/2010
RUE DU MOULIN
LES LEVADES
19600 SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE
50016846300288
(secondaire)
46.73ACréation
1/1/2008
Fermeture
5/13/2011
18 RUE DE MAILLEZAIS
17137 NIEUL-SUR-MER
50016846300023
(secondaire)
46.73ACréation
10/24/2007
Fermeture
6/1/2019
13 RUE GERMAINE TAILLEFERRE
N°13 AU 15
75019 PARIS
50016846300015
(secondaire)
74.1JCréation
9/21/2007
Fermeture
10/24/2007
18 AVENUE D'ALSACE
LES MIROIRS
92400 COURBEVOIE
MARQUES
FRPlanet R l'art d'avoir l'air
02, 09, 169/6/1999Invalid Date
BREVETS
DESSINS ET MODÈLES
ACCORDS D'ENTREPRISES
34254732000032Signature
12/18/2019
Diffusion
4/27/2020
accord collectif relatif au forfait annuel en joursAutres dispositions durée et aménagement du temps de travail
Forfaits (en heures, en jours)