HOLDING SOPREMA
 
UNITÉ LÉGALE
Dénomination SocialeHOLDING SOPREMA
Siège Social15 RUE DE SAINT-NAZAIRE
67100 STRASBOURG
Forme JuridiqueSA à conseil d'administration (s.a.i.)
Immatriculation1/1/1955
N° SIREN558500187
Capital55000000 EUR
Code NAF70.10Z (NAFRev2)
ActivitéActivités des sièges sociaux
Effectif salariéInconnu
TVA IntracommunautaireFR76558500187
HISTORIQUE
6/30/2023Transfert de siège → 55850018700775
11/23/2018Changement de catégorie → économie non sociale
1/3/2013Changement de forme → SA à conseil d'administration (s.a.i.)
1/1/2008Changement d'activité → 70.10Z (NAFRev2)
6/30/2006Changement de dénomination sociale → HOLDING SOPREMA
1/1/2004Changement de dénomination sociale → SOPREMA
12/25/2002Changement d'activité → 45.2K (NAF1993)
1/1/1993Changement de dénomination sociale → SOPREMA SA A CONSEIL DE SURV ET DIRECT
1/1/1955Création → SOPREMA SA à directoire (s.a.i.)
OBSERVATIONS
13/10/2020 Fusion absorption de FIBRASA HOLDING AG société de droit suisse, situé C/° Fidinter AG, Succursale de Zug, Utermüli 7 , 6300 ZUG
REPRÉSENTANTS
typePrésident du conseil d’administrationPierre, Etienne BINDSCHEDLER
né(e) en 12/1961
67100 STRASBOURG
FRANCE
typeAdministrateurJean-claude CUISINIER
né(e) en 05/1935
67300 Schiltigheim
FRANCE
typeAdministrateurElisabeth BINDSCHEDLER
né(e) en 03/1959
67000 Strasbourg
FRANCE
typeCommissaire aux comptes titulaireKPMG AUDIT
9 Avenue de l'Europe
Espace Européen de l'Entreprise
67300 Schiltigheim
typeAdministrateurCRIGEL FRANCE
15 RUE DE SAINT NAZAIRE
67100 STRASBOURG
typeCommissaire aux comptes titulaireCABINET GROSS HUGEL
53 Rue du Général Offenstein
67000 Strasbourg
BÉNÉFICIAIRES
typeL'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF.
Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire.
Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici :
ACTES - (59 actes dans 32 dépôts)
pdfTraite de fusion signe
pdfProcès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire
pdfNyl2ff72aYKJ C0022A1001L346356D20231219H190833TPIJTES003PDBOR
pdfyfcCRYdgX1gx C0022A1001L106813D20230826H182408TPIJTES003PDBOR
pdfxas122ODF7X1 C0022A1001L106816D20230826H172510TPIJTES003PDBOR
pdfProcès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
pdfProcès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Fusion absorption
pdfProcès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Fusion absorption
pdfProjet de traité de fusion
entre la société HOLDING SOPREMA, société anonyme, société absorbante et la société FIBRASA HOLDING AG, société anonyme de droit suisse, société absorbée.
pdfProcès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Augmentation du capital social

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Modification(s) statutaire(s)

Statuts mis à jour
pdfProcès-verbal d'assemblée
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
pdfProcès-verbal d'assemblée
Changement de forme juridique

Procès-verbal d'assemblée
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

Procès-verbal du conseil d'administration

Statuts mis à jour
pdfAC 6752 1955B00018 2011 05660
pdfProcès-verbal du conseil de surveillance
Modifications relatives au directoire et au conseil de surveillance
pdfAC 6752 1955B00018 2010 07753
pdfProcès-verbal du conseil de surveillance
Modifications relatives au directoire et au conseil de surveillance
pdfProcès-verbal d'assemblée
Mise en harmonie des statuts

Statuts mis à jour
Au 19/06/2008
pdfProcès-verbal d'assemblée
nomination de deux membres du conseil de surveillance
pdfDivers
nomination en date du 14.09.2007 d'un nouveau représentant permanent dumembre du conseil de surveillance CRIGEL FRANCE SAS
pdfDivers
EXTRAIT DU PV D'ASSEMBLEE DU 30.6.2006 Changement de dénomination en celle de HOLDING SOPREMA Modification de l'objet social

Déclaration de conformité
Changement de dénomination en celle de HOLDING SOPREMA Modification de l'objet social

Divers
PROJET D'APPORT PARTIEL D'ACTIF ENTRE SOPREMA ET SOPREMA ETANCHEITE Changement de dénomination en celle de HOLDING SOPREMA Modification de l'objet social

Divers
PROJET D'APPORT PARTIEL D'ACTIF ENTRE SOPREMA ET SOPREMA ENTREPRISES Changement de dénomination en celle de HOLDING SOPREMA Modification de l'objet social

Statuts mis à jour
Changement de dénomination en celle de HOLDING SOPREMA Modification de l'objet social
pdfDivers
Projet d'apport partiel d'actif en date du 22/05/2006

Divers
Projet d'apport partiel d'actif conclu entre la société SOPREMA ENTREPRISES(bénéficiaire) et la société SOPREMA S.A. (apporteuse)
pdfDivers
Projet d'apport partiel d'actif en date du 22/05/2006

Divers
Projet d'apport partiel d'actif conclu entre la société SOPREMA ETANCHEITE(bénéficiaire) et la société SOPREMA S.A. (apporteuse)
pdfProcès-verbal du conseil de surveillance
Modification du directoire - conseil de surveillance

Procès-verbal d'assemblée
Modification du directoire - conseil de surveillance
pdfProcès-verbal d'assemblée
Augmentation du capital social

Procès-verbal d'assemblée
Conversion du capital en euros

Statuts mis à jour
pdfProcès-verbal d'assemblée
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES C/COMPTES REMPLACEMENT DU PRDT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE NOMINATION D'UN REPRESENTANT PERMANENT Modification de(s) commissaire(s) aux comptes

Procès-verbal du conseil de surveillance
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES C/COMPTES REMPLACEMENT DU PRDT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE NOMINATION D'UN REPRESENTANT PERMANENT Modification de(s) commissaire(s) aux comptes
pdfDivers
ATTESTATION DE CESSION D'ACTIONS DU 3.9.96 DEPART D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUITE A CESSION DE SES ACTIONS

Procès-verbal d'assemblée
DEPART D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUITE A CESSION DE SES ACTIONS

Statuts mis à jour
DEPART D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUITE A CESSION DE SES ACTIONS
pdfDivers
EXTRAIT DU PV D'ASSEMBLEE DU 29.6.94 NOMINATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
pdfStatuts mis à jour
Modification du directoire - conseil de surveillance

Procès-verbal d'assemblée
Modification du directoire - conseil de surveillance

Procès-verbal du conseil de surveillance
Modification du directoire - conseil de surveillance

Déclaration de conformité
Modification du directoire - conseil de surveillance
pdfProcès-verbal du conseil d'administration

Divers
NOMINATION D'UN VICE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
pdfProcès-verbal d'assemblée
Modifications relatives au conseil d'administration
pdfProcès-verbal du conseil d'administration
Modifications relatives au conseil d'administration
pdfProcès-verbal d'assemblée
NOMINATION D'UN VICE PRESIDENT
pdfSOH - Statuts signe
pdfSOH - Extrait de PV de l AGO - rectification statuts
pdfHOSOP - Extrait du PV de l AG - 13052024
pdfID - Maka TODRIA
COMPTES
Clôture
31/12/2022
Dépôt
30/07/2024
Clôture
31/12/2021
Dépôt
29/08/2022
Clôture
31/12/2020
Dépôt
09/11/2021
Clôture
31/12/2019
Dépôt
10/11/2020
Clôture
31/12/2017
Dépôt
16/10/2018
Clôture
31/12/2016
Dépôt
20/11/2017
BODACC
7/6/2025STRASBOURGVentes et cessions
8/6/2024STRASBOURGDépôts des comptes
6/9/2024STRASBOURGModifications diverses
5/29/2024STRASBOURGModifications diverses
8/6/2024STRASBOURGDépôts des comptes
8/29/2023STRASBOURGModifications diverses
8/29/2023STRASBOURGModifications diverses
9/18/2022STRASBOURGModifications diverses
9/15/2022STRASBOURGDépôts des comptes
11/18/2021STRASBOURGDépôts des comptes
1/2/2021STRASBOURGDépôts des comptes
5/28/2020STRASBOURGVentes et cessions
9/19/2019STRASBOURGDépôts des comptes
1/3/2018STRASBOURGDépôts des comptes
10/26/2018STRASBOURGDépôts des comptes
1/18/2017STRASBOURGDépôts des comptes
12/19/2015STRASBOURGDépôts des comptes
1/27/2014STRASBOURGDépôts des comptes
12/15/2014STRASBOURGDépôts des comptes
12/9/2013STRASBOURGDépôts des comptes
4/11/2013STRASBOURGModifications diverses
4/11/2013STRASBOURGModifications diverses
10/23/2013STRASBOURGModifications diverses
12/9/2013STRASBOURGDépôts des comptes
12/9/2013STRASBOURGDépôts des comptes
7/29/2011STRASBOURGModifications diverses
10/21/2010STRASBOURGModifications diverses
10/14/2009STRASBOURGDépôts des comptes
10/24/2008STRASBOURGDépôts des comptes
4/8/2008STRASBOURGModifications diverses
2/24/2008STRASBOURGModifications diverses
ETABLISSEMENTS
55850018700775
(siège)
70.10ZCréation
6/12/2023
 15 RUE DE SAINT-NAZAIRE
67100 STRASBOURG
55850018700767
(secondaire)
45.2KCréation
6/30/2006
Fermeture
6/30/2006
31 IMPASSE MICHEL ANGE
31200 TOULOUSE
55850018700759
(secondaire)
45.2KCréation
8/1/2004
Fermeture
6/30/2006
34 RUE ROBERT SCHUMAN
ZAC DU BREUIL
54850 MESSEIN
55850018700742
(secondaire)
45.2KCréation
8/19/2003
Fermeture
6/30/2006
VOIE DU FUTUR
PARC D'AFFAIRES DES PORTES
27100 VAL-DE-REUIL
55850018700726
(secondaire)
45.2KCréation
4/1/2003
Fermeture
6/30/2006
RUE GEORGES BRASSENS
CRT N 3
59273 FRETIN
55850018700718
(secondaire)
45.2KCréation
12/17/2001
Fermeture
6/30/2006
27 RUE JACQUES MUGNIER
ZAC PARC DES COLLINES
68200 MULHOUSE
55850018700700
(secondaire)
45.2KCréation
1/1/2001
Fermeture
6/30/2006
26 RUE MAUPERTUIS
29200 BREST
55850018700692
(secondaire)
26.8CCréation
5/10/2000
Fermeture
6/30/2006
35 AVENUE JOHN FITZGERALD KENNEDY
17100 SAINTES
SOPREMA EXPORT
55850018700684
(secondaire)
45.2KCréation
3/1/2000
Fermeture
12/25/2002
PESQUE
ESPACE CRISTAL BATIMENT 3
64140 LONS
55850018700676
(secondaire)
45.2KCréation
1/1/2000
Fermeture
6/30/2006
6 RUE DE BRETIGNY
28630 GELLAINVILLE
55850018700643
(secondaire)
45.2KCréation
7/1/1999
Fermeture
6/30/2006
5 RUE DES FRERES DE MONTGOLFIER
ESP. ACT. DE KERMELIN
56890 SAINT-AVE
55850018700668
(secondaire)
45.2KCréation
5/1/1999
Fermeture
6/30/2006
66 ROUTE DE LA FRUITIERE
ZA LES CHAMOUX
74650 CHAVANOD
55850018700650
(secondaire)
45.2KCréation
4/1/1997
Fermeture
6/30/2006
11 RUE DE LA TUILERIE
CENTRE D'ACTIVITE
70400 HERICOURT
55850018700635
(secondaire)
51.5FCréation
11/2/1993
Fermeture
6/30/2006
92 BOULEVARD VICTOR HUGO
IMM CLICHY POUCHET 092-098
92110 CLICHY
55850018700627
(secondaire)
45.2KCréation
7/1/1993
Fermeture
6/30/2006
RUE CHARLES NUNGESSER
ZAC MAS DES CAVALIERS
34130 MAUGUIO
55850018700619
(secondaire)
51.5FCréation
6/10/1992
Fermeture
6/30/2006
610 RUE DU GRAND GIGOGNAN
LE FORUM DE COURTINE
84000 AVIGNON
55850018700601
(secondaire)
45.2KCréation
3/3/1992
Fermeture
6/30/2006
125 RUE DES 4 GENDARMES D’OUVEA
84000 AVIGNON
55850018700593
(secondaire)
45.2KCréation
10/1/1991
Fermeture
6/30/2006
AVENUE ARNAUD DE VOGUE
LES QUATRE VENTS
18000 BOURGES
55850018700585
(secondaire)
45.2KCréation
6/17/1991
Fermeture
6/30/2006
7 RUE JEAN-BAPTISTE PERRIN
33320 EYSINES
55850018700577
(secondaire)
45.2KCréation
3/14/1991
Fermeture
5/10/2000
20 RUE DE LA GARENNE
16160 GOND-PONTOUVRE
55850018700569
(secondaire)
45.2KCréation
3/14/1991
Fermeture
6/30/2006
ZA LA FORET
72470 CHAMPAGNE
55850018700544
(secondaire)
45.2KCréation
4/2/1990
Fermeture
12/31/1997
AIRE INDUST ND ROUSSILLON
PLEIN SUD ENTREPRISES
66600 RIVESALTES
55850018700536
(secondaire)
45.2KCréation
6/5/1989
Fermeture
6/30/2006
3 RUE LOUIS LACHENAL
69740 GENAS
55850018700528
(secondaire)
45.2KCréation
12/1/1988
Fermeture
6/30/2006
5 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
63360 GERZAT
55850018700478
(secondaire)
45.2KCréation
4/30/1987
Fermeture
12/25/1993
LA CALADE
CD 132
34970 LATTES
55850018700502
(secondaire)
26.8CCréation
1/1/1987
Fermeture
12/25/1992
3 AVENUE DE LA SYNAGOGUE
IMMEUBLE LE BONAVENTURE
84000 AVIGNON
55850018700452
(secondaire)
45.2KCréation
3/24/1986
Fermeture
6/30/2006
19 RUE GABRIEL VOISIN
51100 REIMS
55850018700460
(secondaire)
45.2KCréation
1/2/1986
Fermeture
6/30/2006
ROUTE DE BODEN
29500 ERGUE-GABERIC
55850018700445
(secondaire)
45.2KCréation
9/17/1984
Fermeture
6/30/2006
16 AVENUE DE NIMES
30320 MARGUERITTES
55850018700429
(secondaire)
70.10ZCréation
12/1/1981
Fermeture
1/1/2008
AVENUE FREDERIC ET IRENE JOLIOT CURIE
64140 LONS
55850018700551
(secondaire)
45.3ECréation
1/1/1977
Fermeture
3/3/1992
37 RUE MANTEL
84000 AVIGNON
55850018700064
(secondaire)
45.2KCréation
1/1/1900
Fermeture
12/25/1993
1 RUE DU DEPART
75014 PARIS
55850018700361
(secondaire)
45.2KCréation
1/1/1900
Fermeture
6/30/2006
19 RUE DE BEL AIR
ZONE INDUSTRIELLE
44470 CARQUEFOU
55850018700288
(secondaire)
45.2KCréation
1/1/1900
Fermeture
6/30/2006
22 RUE DE LA CROIX DU BOURDON
86000 POITIERS
55850018700155
(secondaire)
45.2KCréation
1/1/1900
Fermeture
6/30/2006
21 RUE DU NOYER
35000 RENNES
55850018700338
(secondaire)
45.2KCréation
1/1/1900
Fermeture
6/30/2006
AVENUE ARISTIDE BERGES
38420 DOMENE
55850018700403
(secondaire)
45.2KCréation
1/1/1900
Fermeture
4/1/2003
2 CHEMIN DES DEUX TILLEULS
59810 LESQUIN
55850018700130
(secondaire)
45.2KCréation
1/1/1900
Fermeture
12/25/1995
RUE DU MOULIN
51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE
55850018700239
(secondaire)
45.2KCréation
1/1/1900
Fermeture
6/30/2006
5 IMPASSE EDOUARD BELIN
21300 CHENOVE
55850018700056
(secondaire)
26.8CCréation
1/1/1900
Fermeture
6/30/2006
5 RUE MOURRE
84000 AVIGNON
55850018700098
(secondaire)
70.10ZCréation
1/1/1900
Fermeture
6/12/2023
14 RUE DE SAINT-NAZAIRE
67100 STRASBOURG
55850018700197
(secondaire)
26.8CCréation
1/1/1900
Fermeture
8/19/2003
RUE DU CANAL
27400 LOUVIERS
55850018700171
(secondaire)
45.2KCréation
1/1/1900
Fermeture
6/30/2006
31 IMPASSE MICHEL ANGE
31200 TOULOUSE
55850018700411
(secondaire)
45.2KCréation
1/1/1900
Fermeture
6/30/2006
62 RUE TRANSVERSALE
92230 GENNEVILLIERS
55850018700080
(secondaire)
45.2KCréation
1/1/1900
Fermeture
12/31/2001
116 RUE DE PFASTATT
68260 KINGERSHEIM
55850018700114
(secondaire)
45.2KCréation
1/1/1900
Fermeture
8/1/2004
3 RUE DU STADE
54220 MALZEVILLE
55850018700106
(secondaire)
45.2KCréation
1/1/1900
Fermeture
6/30/2006
6 RUE DES FEIVRES
57070 METZ
55850018700734
(secondaire)
45.2KCréation
1/1/1900
Fermeture
12/25/2002
2 AVENUE JOSEPH MARIE JACQUARD
64140 LONS